home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Hackers Underworld 2: Forbidden Knowledge / Hackers Underworld 2: Forbidden Knowledge.iso / LEGAL / ALCOR3.TXT < prev    next >
Text File  |  1994-07-17  |  22KB  |  475 lines

  1. Ok folks, as I promised, here are the legal papers filed in the email  
  2. case since the original filing.  Typos are most likely mine.  Comments  
  3. are in [brackets], skipping the first few pages is recommened.  Sorry it  
  4. took so long, I recieved copies of this stuff only yesterday.  
  5.      ---Keith Henson
  6.  
  7.  
  8. KINKEL, RODIGER & SPRIGGS 
  9.   BRUCE DISENHOUSE 
  10. 3393 Fourteenth Street 
  11. Riverside, CAlifornia  92501 
  12. (714) 683-2410 
  13.  
  14. GREINES, MARTIN, STEIN & RICHLAND 
  15.   MARTIN STEIN 
  16. 9601 Wilshire Boulevard, Suite 544 
  17. Beverly Hills, California  90210-5215 
  18. (213) 859-7811 
  19.  
  20.  
  21. Attorney for Defendants County of Riverside, Grover C. Trask, II, Curtis  
  22. R. Hinman, Raymond Carrillo, Robert Spitzer and John V. Mosley y
  23.  
  24. UNITED STATES DISTRICT COURT 
  25. FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA 
  26.  
  27.  
  28. H. KEITH HENSON, et al.,  
  29.  
  30. Plaintiffs, 
  31.  
  32. vs. 
  33.  
  34. Raymond Carrillo, et al., 
  35.  
  36. Defendants. 
  37.  
  38. Case No. SA CV 90-021 JSL (RwRx) 
  39.  
  40. NOTICE OF MOTION AND MOTION  
  41. TO DISMISS COMPLAINT FOR 
  42. DECLARATORY RELIEF AND 
  43. DAMAGES (Electronic 
  44. Communication Privacy Act of 1986; 
  45. 18 U.S.C. Section 2701, et seq.)  PURSUANT
  46. TO RULE 12 (b), F.R.C.P.; 
  47. MEMORANDUM OF POINTS AND 
  48. AUTHORITIES IN SUPPORT 
  49. THEREOF 
  50.  
  51. Date:  April 30, 1990 
  52. Time:  1:00 p.m. 
  53. Courtroom:  No. 2 
  54. Trial Date:  None set 
  55.  
  56.  
  57.  
  58. TABLE OF CONTENTS 
  59.  
  60.  
  61. MOTION TO DISMISS COMPLAINT FOR DECLARATORY RELIEF AND DAMAGES 
  62. (ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT OF 1986; U.S.C. Section 
  63. 2701, et seq.)         Page 3 
  64.  
  65.  
  66.  
  67. MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES    page 5 
  68.  
  69. INTRODUCTION AND STATEMENT OF RELEVANT FACTS      page 5 
  70.  
  71. LEGAL DISCUSSION    page 7 
  72.  
  73.  
  74.  
  75. I.    THE COMPLAINT SHOULD BE DISMISSED AS TO ALL NAMED DEFENDANTS 
  76. BECAUSE PLAINTIFFS HAVE FAILED TO STATE A CLAIM FOR RELIEF UNDER 
  77. THE ELECTRONIC COMMUNICATION PRIVACY ACT.    page   7  
  78.  
  79.  
  80.  
  81. II.  EVEN IF THIS COURT WERE TO CONCLUDE THAT THE SEARCH WARRANT 
  82. WAS TECHNICALLY DEFICIENT, STILL DEFENDANTS ARE PROTECTED FROM 
  83. SUIT BY THE DOCTRINE OF GOD-FAITH RELIANCE.  THUS THE COMPLAINT 
  84. SHOULD BE ORDERED DISMISS ON THIS ADDITIONAL GROUND.  page 11 
  85.  
  86.  
  87. CONCLUSION   page 13 
  88.  
  89. TABLE OF AUTHORITIES 
  90.  
  91. Cases 
  92.  
  93. Burrows v. Superior Court      page 10 
  94.    13 Cal.3d 238  (1974) 
  95.  
  96. Harlow v. Fitzgerald,              page 12 
  97.    457 U.S. 800  (1982) 
  98.  
  99. People v. Dumas,                 page 10
  100.     Cal.3d 871 (1973) 
  101.  
  102. Robison v. Via,                   page   12 
  103.     821 f.2d 913 (2d Cir. 1987) 
  104.  
  105. Tomer v. Gates          page  12 
  106.    811 f.2d 1240 (9th Cir.  1987) 
  107.  
  108. U.S. v. McLaughlin, 
  109.     851 f.2d 283 (9th Cir. 1986) 
  110.  
  111. U.S. v. Michaelian, 
  112.     803 f.2d 1042 (9th Cir. 1986) 
  113.  
  114. U.S. v. Spilotro 
  115.      800 f.2d 959 (9th Cir. 1986) 
  116.  
  117. Statues 
  118.  
  119. 18 U.S.C.  Section 2701 
  120. 18 U.S.C.  Section 2707 
  121.  
  122. Constitutions 
  123.  
  124. Unites state Constitution, Fourth Amendment 
  125.  
  126. Rules 
  127.  
  128. Federal Rules of Civil Procedure, Rule 12(b) 
  129. United States District Court for the 
  130. Central District of California, 
  131.  
  132. Local Rule 7.6 
  133. Local Rule 7.9 
  134.  
  135. Misc. 
  136.  
  137. 1986 U.S Cond Cong Adm Nes, Ann. 
  138.  
  139. TO PLAINTIFFS H. KEITH HENSON, ET AL., AND THEIR ATTORNEYS OF RECORD: 
  140.  
  141.       PLEASE TAKE NOTICE that on April 30, 1990 at 1:00 p.m.  or as soon
  142. thereafter as the matter may be heard in Courtroom 2 of the Honorable J. 
  143. Spencer Letts, Judge of the United states district Court for the Central 
  144. District of California, 751 Santa Ana Boulevard, Santa Ana, California 
  145. 92701-4599, defendants County of Riverside, Grover C Trask, II, Curtis R. 
  146. Hinman, Raymond Carrillo, Robert Spitzer, and John V. Mosley will bring on 
  147. for hearing the accompanying Motion to Dismiss complaint for Declaratory 
  148. Relief, and Damages (Electronic Communication Privacy Act of 1986; 18 
  149. U.S.C. Section 2701, et seq.). 
  150.  
  151.       Defendants' motion will be brought pursuant to Rule 12(b) of the  
  152. Federal Rules of Civil Procedure and will be based on this Notice of  
  153. Motion and Motion, the attached memorandum of ports and authorities, and 
  154. on such other and further documentation evidence and argument as may be  
  155. presented in support of this motion.  
  156.       
  157.      PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that under Local Rule 7.6 of the United  
  158. States District Court for the Central District of California, a party  
  159. opposing a motion shall, not later than 14 days before the date set for  
  160. hearing of the motion, serve upon all parties and file with the clerk of  
  161. the court either (a) a brief, but complete memorandum containing a  
  162. statement of all reasons in opposition to said motion, and the point and  
  163. authorities upon which the opposition party will rely, or (b) a written  
  164. statement that he will not oppose the motion.  Under Local Rule 7.9,  
  165. failure to file any required papers may be deemed by the court consent to  
  166. the granting of the motion.   
  167.  
  168. Dated:  March 27, 1990. 
  169.  
  170. Respectfully submitted, 
  171.  
  172. [boilerplate] 
  173.  
  174. [signed] Martin Stein 
  175.  
  176. [page 3] 
  177.  
  178. MOTION TO DISMISS COMPLAINT FOR DECLARATORY RELIEF AND DAMAGES 
  179. (ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT OF 1986; 18 U.S.C. Section 
  180. 2701, et seq.)  
  181.  
  182.  
  183.      Pursuant to the provisions of rule 12(b) of the Federal Rules of  
  184. Civil Procedure, defendants [list], hereby move to dismiss the Complaint  
  185. for declaratory relief and damages on file herein on the following  
  186. separate grounds:  
  187.  
  188.      1.    Plaintiffs have failed to allege sufficient facts to state a a
  189. claim for relief against the named defendants herein in that the  
  190. allegations of the Complaint and attached documentation establish as a  
  191. matter of law that defendant did not violate the provision of the ECPA in  
  192. execution a facially valid search warrant.  
  193.  
  194.      2.    Even assuming that a technical violation of the ECPA has  
  195. properly been alleged by the plaintiffs in the instant case, the named  
  196. defendants herein are entitled to dismissal on the basis of their  
  197. good-faith reliance on the terms of a facially valid search warrant,  
  198. pursuant to the provisions of 18 U.S.C. section 2707(d)(1).  
  199.  
  200.       WHEREFORE, defendants [list] and each of the pray as follows: 
  201.  
  202.      1.    That each of their motions to dismiss the Complaint be granted  
  203. without leave to amend;  
  204.  
  205.      2.    The the Complaint and each claim for relief alleged therein be  
  206. ordered dismissed as against each of these defendants;  
  207.  
  208.      3.   That plaintiffs be ordered to take nothing from defendants; 
  209.  
  210.      4.   That defendants be awarded judgement for their cost of suit  
  211. incurred herein;  
  212.  
  213.      5.   That this court grant such other and further relief as it deems  
  214. just and proper.  
  215.  
  216.  
  217. Dated:  March 27, 1990 
  218.  
  219. [boiler plate/signed Martin Stein] 
  220.  
  221. [page 5] 
  222.  
  223. _MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES_        
  224.  
  225. _INTRODUCTION AND STATEMENT OF RELEVANT FACTS_      
  226.  
  227.      Plaintiffs seek damages and injunctive relief based on the purported  
  228. acts of the named defendants herein in executing a facially valid search  
  229. warrant.  The assert that in executing the search warrant, defendants  
  230. violated the provisions of the ECPA.  More specifically, plaintiffs  
  231. allege that at some unspecified date prior to January 12, 1988,  
  232. defendants procured from the Riverside County Superior Court a search  
  233. warrant which authorized, in general, a search of the facilities of  
  234. Alcor.  Plaintiffs assert, however, that the search warrant did not  
  235. purport to reach, nor was it intended to reach any of plaintiffs E_Mail.   
  236. Complaint [paragraph] 5. 
  237.  
  238. [footnote--Plaintiffs assert that E-Mail was the facilitation, sending  
  239. and receipt of electronic mail via computerized modems.  Complaint, para 
  240. 4]  
  241.  
  242. Plaintiffs assert that pursuant to the search warrant, on January 12,  
  243. 1988, defendants searched Alcor's premises and removed a variety of items  
  244. including the electronic media containing plaintiffs E-Mail.  Complaint  
  245. [paragraph] 6.  Plaintiffs conclude by alleging that notwithstanding that  
  246. defendants and each of the were informed that they had taken, along with  
  247. materials described the warrant, E-Mail belonging to plaintiffs, that  
  248. defendants herein knowingl